Home
Search
Print
Bookmark
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Contents
Home
About this Website
What's New
Surnames
Places
Sources
Repositories
Dates and Anniversaries
Cemeteries
Headstones
Photos
Histories and Events
Documents
Notes
Reports
Statistics
Most Wanted
Bookmarks
DNA Projects
Contact Us
Contact Form
Search
Last Name:
First Name:
Advanced Search
GenDex Network
Family Tree Seeker
TNG
version: 15.0.2
________ Mann
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
________ Mann
[1]
2
Maude Mann
[1.1]
William Brewster
3
William Brewster
[1.1.1]
b. Abt 1535 d. 1590
Mary Smythe
4
Elder William Brewster
[1.1.1.1]
b. 1566 d. 10 Apr 1644
Mary Wentworth
b. Abt 1569 d. 17 Apr 1627
5
Jonathan Brewster
[1.1.1.1.1]
b. 12 Aug 1593 d. 7 Aug 1659
Lucretia Oldham
b. Jan 1600 d. 4 Mar 1678/9
6
William Brewster
[1.1.1.1.1.1]
b. 9 Mar 1625 d. Bef 1658
6
Mary Brewster
[1.1.1.1.1.2]
b. 16 Apr 1627 d. Aft 23 Mar 1697/8
John Turner, Sr.
b. Abt 1620 d. Between 4 Mar 1695 and 20 May 1697
7
Jonathan Turner
[1.1.1.1.1.2.1]
b. 20 Sep 1646 d. 18 Apr 1724
+
Mercy Hatch
b. 15 Apr 1665 d. Between 26 Oct 1714 and 21 Aug 1721
7
Lydia Turner
[1.1.1.1.1.2.2]
b. 24 Jan 1652 d. 20 Jun 1714
+
John James
b. SAY 1646 d. Between 26 Feb 1677/8 and 5 Mar 1678/9
6
Jonathan Brewster
[1.1.1.1.1.3]
b. 17 Jul 1629 d. Aft Jun 1650
6
Ruth Brewster
[1.1.1.1.1.4]
b. 3 Oct 1631 d. 1 May 1677
John Pickett
d. 16 Aug 1667
7
Ruth Pickett
[1.1.1.1.1.4.1]
b. Abt 1653/4 d. 14 Sep 1690
+
Rev. Moses Noyes
b. 16 Dec 1643 d. 10 Nov 1729
6
Capt. Benjamin Brewster
[1.1.1.1.1.5]
b. 17 Nov 1633 d. 14 Sep 1710
Anne Addis
d. 9 May 1709
7
Mary Brewster
[1.1.1.1.1.5.1]
b. 10 Dec 1660 d. 2 Dec 1750
7
Ann Brewster
[1.1.1.1.1.5.2]
b. 29 Sep 1662 d. Aft Jun 1718
Matthew Coy
b. 5 Sep 1656 d. Aft 11 Jun 1718
8
Daniel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.1]
b. 15 Jun 1685
8
Jonathan Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2]
b. 6 May 1687 d. 10 Feb 1766
Abigail ________
b. Abt 1690 d. 12 Jun 1767
9
Jonathan Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.1]
9
Samuel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.2]
b. 1717
+
Elizabeth Jacobs
b. 14 Mar 1711/2
9
Abiah Coye
[1.1.1.1.1.5.2.2.3]
b. Abt 1720 d. Bef 24 Jun 1783
9
Mary Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.4]
9
Moses Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.5]
9
John Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.6]
+
Sarah Luce
b. Abt 1723 d. 8 Dec 1763
9
Matthew Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.7]
9
Nathaniel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.8]
9
Abigail Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.9]
b. 8 Nov 1731
9
Joseph Coy
[1.1.1.1.1.5.2.2.10]
8
Ruth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.3]
b. 7 Oct 1689 bur. 25 Oct 1752
8
Matthew Coy, Jr.
[1.1.1.1.1.5.2.4]
b. Abt 1692
Sarah Welch
b. 15 Nov 1698
9
Ann Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.1]
9
Sarah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.2]
9
Daniel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.3]
b. 17 Jun 1722
9
Matthew Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.4]
b. Abt 1724 d. 8 May 1776
9
John Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.5]
9
Elizabeth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.6]
9
Benjamin Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.7]
+
Mary Cottriel
9
Ephraim Coy
[1.1.1.1.1.5.2.4.8]
8
Mary Coy
[1.1.1.1.1.5.2.5]
b. Abt 1693
8
Samuel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6]
b. 16 Feb 1697/8 d. 1776
Elizabeth Read
b. 5 Apr 1698 d. 1766
9
Abraham Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1]
b. 22 Dec 1718 d. 17 Jun 1795
Abigail Pease
b. 22 Sep 1722 d. 5 Nov 1801
10
Zipporah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.1]
b. 20 May 1744
10
Abigail Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.2]
10
Elisabeth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.3]
10
Prudence Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.4]
b. 1 Apr 1755
10
Abraham Coy, Jr.
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.5]
b. 27 May 1757 d. 30 Sep 1778
+
Jerusha Kibbe
b. 6 Aug 1757 d. 15 Jun 1840
10
Anna Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.6]
b. 4 Jun 1759
10
Miriam Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.1.7]
b. 4 Jun 1759
9
Zipporah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.2]
b. 11 Apr 1720
9
Samuel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.3]
b. 5 Mar 1723 d. 6 Apr 1778
Sarah Hall
b. 31 May 1732 d. 29 May 1782
10
Sarah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.3.1]
b. 23 Jan 1755
10
Mabel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.3.2]
b. 5 Feb 1757 d. 31 Oct 1823
10
Josiah McCoy
[1.1.1.1.1.5.2.6.3.3]
b. 31 Jan 1764 d. 17 Sep 1834
10
Temphena Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.3.4]
b. 3 Jan 1766 d. 10 Apr 1838
9
Elizabeth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.4]
b. 3 May 1726
9
Josiah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.5]
b. Abt 1728
9
David Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.6]
b. 23 Jan 1730/1 d. Abt 14 Apr 1805
Abigail Follett
b. 18 Aug 1737 d. Abt 1808
10
David Coy, Jr.
[1.1.1.1.1.5.2.6.6.1]
b. 19 May 1759 d. 16 Dec 1854
10
Anna Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.6.2]
b. Abt 1767 d. Apr 1850
10
Comfort Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.6.3]
b. 6 Mar 1774 d. 30 May 1852
+
Abigail Burdett
b. Abt 1784 d. 24 Jun 1864
10
Lucretia Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.6.4]
b. 1 Nov 1777
10
Samuel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.6.5]
b. Abt 1781
9
Uriah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.7]
b. 4 Aug 1734 d. 1817
Anna Brace
b. 2 Jul 1736 d. 14 Nov 1825
10
Eunice Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.7.1]
b. 4 Dec 1758
10
Hannah Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.7.2]
b. 8 Sep 1761
10
Silas Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.7.3]
9
Corp. Silas Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8]
b. 14 Sep 1737 d. 22 Sep 1762
Deborah Hall
b. 28 Oct 1735 d. 25 Apr 1818
10
Corp. Edward Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1]
b. 14 Oct 1761 d. 21 Aug 1830
Flavia Martha Gibson
b. 2 Sep 1765 d. 8 May 1832
11
Jonathan Silas Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.1]
b. 9 Apr 1787 d. 24 Dec 1814
11
Samuel Crowfoot Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.2]
b. 26 Nov 1788 d. 5 Nov 1822
Mary P. Finch
b. 13 Jul 1793 d. 14 Mar 1884
12
Joseph Edee Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.2.1]
b. Abt 1819 d. 8 May 1861
11
Cynthia Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.3]
b. 6 Jul 1791 d. 19 Apr 1869
+
Stephen Bristol
b. 25 Feb 1787 d. 25 Feb 1874
11
Louisa F. Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.4]
b. 30 Jun 1793 d. 10 Jun 1863
+
Levi Webster
b. 29 May 1787 d. 24 May 1865
11
Pamelia Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.5]
b. 10 May 1795 d. Between 1870 and 1880
+
Alanson Corbin
b. Abt 1794 d. Between 1870 and 1880
11
Gibson Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.6]
b. 10 Apr 1797 d. 24 Jul 1886
+
Marinda Sweet
b. 2 Jun 1802 d. 14 Nov 1897
11
Flavia Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.7]
b. 30 Mar 1799 d. 9 Jul 1890
+
Henry McAlpine
b. 1799 d. 1887
11
John R. Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.8]
b. 11 May 1801 d. 24 Mar 1884
Mary P. Finch
b. 13 Jul 1793 d. 14 Mar 1884
12
Flavia Joanna Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.8.1]
b. 10 Apr 1827 d. 28 Apr 1911
12
Celeste Jenet Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.8.2]
b. 7 Jan 1833
12
Sarah Elizabeth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.8.3]
b. 3 Jan 1839
11
Johanna D. Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.9]
b. 12 Jul 1803 d. 10 Aug 1888
+
Henry Whitbeck
b. 1789 d. Jun 1860
11
Mercy Gipson Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.10]
b. 28 Jul 1805 d. 28 Dec 1891
11
Pvt. Silas Edee Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11]
b. 21 Oct 1807 d. 17 Dec 1889
Lorinda Willard
b. 27 Aug 1812 d. 22 Dec 1891
12
Samuel Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.1]
d. young
12
Willard F. Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.2]
b. 15 Nov 1834 d. 28 Mar 1922
12
Vitruvius Darius Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.3]
b. 23 Dec 1838 d. 27 Dec 1917
12
Mary Gibson Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.4]
b. Abt 1841 d. 20 May 1847
12
Rosamund Penelope Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.5]
b. 8 Jan 1844 d. 7 Feb 1906 [
=>
]
12
Flavia Matilda Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.6]
b. 8 Oct 1845 d. 19 Oct 1920
12
Grace Thankful Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.7]
b. 25 Apr 1847 d. 22 Jul 1922
12
Joseph Edee Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.8]
b. 23 Apr 1851 d. 24 Apr 1931
12
Annette M. Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.9]
b. 9 Feb 1852 d. 26 May 1938 [
=>
]
12
Silas Erwin Coy
[1.1.1.1.1.5.2.6.8.1.11.10]
b. 14 Aug 1854 d. 28 Sep 1923 [
=>
]
8
Elizabeth Coy
[1.1.1.1.1.5.2.7]
7
Jonathan Brewster
[1.1.1.1.1.5.3]
b. 30 Nov 1664 d. 20 Nov 1704
7
Capt. Daniel Brewster
[1.1.1.1.1.5.4]
b. 1 Mar 1666/7 d. 7 May 1735
+
Hannah Gager
b. Feb 1666 d. 25 Sep 1727
7
William Brewster
[1.1.1.1.1.5.5]
b. 22 Mar 1669 d. 11 Aug 1728
+
Elizabeth Read
b. Nov 1672 d. 11 Mar 1692/3
7
Ruth Brewster
[1.1.1.1.1.5.6]
b. 16 Sep 1671 d. 22 Aug 1734
7
Benjamin Brewster
[1.1.1.1.1.5.7]
b. 25 Dec 1673 d. 31 Jan 1755
+
Mary Smith
b. 28 Nov 1672 d. 27 Mar 1747
7
Elizabeth Brewster
[1.1.1.1.1.5.8]
b. 23 Jun 1676 d. 9 Mar 1744
6
Elizabeth Brewster
[1.1.1.1.1.6]
b. 1 May 1637 d. Feb 1708
6
Grace Brewster
[1.1.1.1.1.7]
b. 1 Nov 1639 d. 22 Apr 1684
6
Hannah Brewster
[1.1.1.1.1.8]
b. 3 Nov 1641 d. Aft 25 Nov 1691
+
Samuel Starr
b. Abt 1640/1 d. Bef 2 Feb 1687/8
5
Patience Brewster
[1.1.1.1.2]
b. Abt 1600 d. 1634
Gov. Thomas Prence
b. Abt 1600 d. 29 Mar 1673
6
Rebecca Prence
[1.1.1.1.2.1]
b. SAY 1625 d. Bef 18 Jul 1651
Edmund Freeman, Jr.
b. 1620 d. Bef 5 Jan 1703/4
7
Patience Freeman
[1.1.1.1.2.1.1]
b. Abt 1647 d. Aft 9 Mar 1725/6
+
Joseph Burgess
b. 1637 d. Aug 1695
7
Rebecca Freeman
[1.1.1.1.2.1.2]
b. Bef Jul 1651 d. 16 Apr 1738
+
Ezra Perry
b. 11 Feb 1652/3 d. 30 Jan 1729/30
6
Thomas Prence
[1.1.1.1.2.2]
b. SAY 1627
6
Hannah Prence
[1.1.1.1.2.3]
b. SAY 1629 d. Bef 23 Nov 1698
+
Nathaniel Mayo
+
Jonathan Sparrow
b. Abt 1629 d. 21 Mar 1706/7
6
Mercy Prence
[1.1.1.1.2.4]
b. SAY 1631 d. 28 Sep 1711
Maj. John Freeman
b. Abt 1626/7 d. 28 Oct 1719
7
Deacon Thomas Freeman
[1.1.1.1.2.4.1]
b. Sep 1653 d. 9 Feb 1715/6
+
Rebecca Sparrow
b. 30 Oct 1655 d. 7 Feb 1740
5
Fear Brewster
[1.1.1.1.3]
b. Abt 1606 d. Bef 12 Dec 1634
Isaac Allerton
b. Abt 1587 d. Feb 1658/9
6
Sarah Allerton
[1.1.1.1.3.1]
b. Abt 1626/7 d. Bef 1651
6
Isaac Allerton
[1.1.1.1.3.2]
b. Between 22 May 1627 and 1630 d. Between 25 Oct 1702 and 30 Dec 1702
Elizabeth Willoughby
b. Abt 1635 d. Aft Apr 1672
7
Sarah Allerton
[1.1.1.1.3.2.1]
b. Abt 1670/1 d. 17 May 1731
+
Hancock Lee
b. Abt 1653 d. 25 May 1709
5
child Brewster
[1.1.1.1.4]
b. 1609 d. 20 Jun 1609
5
Love Brewster
[1.1.1.1.5]
b. Abt 1611 d. 1 Oct 1650
Sarah Collier
b. Apr 1616 d. 26 Apr 1691
6
Sarah Brewster
[1.1.1.1.5.1]
b. Abt 1635 d. Between 5 Mar 1667/8 and 21 Jan 1678/9
Benjamin Bartlett, Sr.
b. SAY 1629 d. Between 21 Aug 1691 and 28 Aug 1691
7
Benjamin Bartlett, Jr.
[1.1.1.1.5.1.1]
b. Bef 1660 d. Bef 10 Apr 1724
+
Ruth Pabodie
b. 27 Jun 1658 d. 27 Aug 1740
7
Ebenezer Bartlett
[1.1.1.1.5.1.2]
b. Bef Aug 1670 d. Bef 1 Mar 1697/8
+
Hannah Bryant
b. 2 Dec 1668 d. Aft 15 Aug 1725
6
Deacon William Brewster
[1.1.1.1.5.2]
b. Abt 1645 d. 3 Nov 1723
+
Lydia Partridge
b. SAY 1651 d. 2 Feb 1742/3
6
Wrestling Brewster
[1.1.1.1.5.3]
d. 1 Jan 1696/7
+
Mary ________
b. 15 Nov 1661 d. 12 Nov 1742
5
Wrestling Brewster
[1.1.1.1.6]
b. Abt 1614 d. Bef 1644
Prudence Peck
4
Rev. James Brewster
[1.1.1.2]
b. Abt 1568 d. 1613
4
Prudence Brewster
[1.1.1.3]
4
Rev. John Brewster
[1.1.1.4]
b. Abt 1575 d. 14 Aug 1656
________ ________
d. 23 Feb 1657/8
5
Katherine Brewster
[1.1.1.4.1]
b. 1626 d. 23 Aug 1657
Jonathan Higley
b. 1624 d. 1664
6
Capt. John Higley, Sr.
[1.1.1.4.1.1]
b. 22 Jul 1649 d. 25 Apr 1714
Hannah Drake
b. 8 Aug 1653 d. 4 Aug 1694
7
John Higley, Jr.
[1.1.1.4.1.1.1]
b. 6 Aug 1673 d. 1 Dec 1741
7
Jonathan Higley
[1.1.1.4.1.1.2]
b. 16 Feb 1675/6 d. May 1716
7
Hannah Higley
[1.1.1.4.1.1.3]
b. 13 Mar 1677/8 d. 17 Mar 1677/8
7
Katherine Higley
[1.1.1.4.1.1.4]
b. 7 Aug 1679 d. 7 Mar 1740/1
7
Ens. Brewster Higley, Sr.
[1.1.1.4.1.1.5]
b. 1680/1 d. 5 Nov 1760
Hester Holcomb
b. Feb 1684 d. 17 Dec 1775
8
Ens. Brewster Higley, Jr.
[1.1.1.4.1.1.5.1]
b. 12 Dec 1709 d. 21 Mar 1794
8
David Higley
[1.1.1.4.1.1.5.2]
b. 1712 d. Abt 1790
8
Capt. Joseph Higley, Sr.
[1.1.1.4.1.1.5.3]
b. 21 Oct 1715 d. May 1790
8
Hannah Higley
[1.1.1.4.1.1.5.4]
b. 17 Dec 1717 d. 26 Jan 1806
Elijah Owen
b. 7 Oct 1706 d. 22 Sep 1741
9
Hannah Owen
[1.1.1.4.1.1.5.4.1]
b. 17 Jul 1740 d. 18 May 1831
+
Capt. John Brown
b. 4 Nov 1728 d. 3 Sep 1776
8
Hester Higley
[1.1.1.4.1.1.5.5]
b. 3 Dec 1719 d. 15 Sep 1807
8
John Higley, Sr.
[1.1.1.4.1.1.5.6]
b. 17 Feb 1721/2 d. May 1802
Apphia Humphrey
b. 9 May 1726 d. 27 Aug 1762
9
Apphia Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.1]
b. 27 Mar 1747 d. 1783
9
John Higley, Jr.
[1.1.1.4.1.1.5.6.2]
b. 14 Feb 1748/9 d. May 1802
Miriam Dibble
b. 9 Dec 1753 d. 23 Dec 1801
10
Hannah Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.1]
b. 25 Mar 1773
10
John Higley, III
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2]
b. 12 Nov 1774 d. 1 May 1833
Diadama Messenger
b. 1 Apr 1780 d. 28 Mar 1830
11
Apphia Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.1]
b. 23 Aug 1798 d. 5 Nov 1820
11
Pamelia Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2]
b. 25 May 1800 d. 26 Jan 1888
John Sturdevant
b. Abt 1797 d. 22 Nov 1853
12
Emeline Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.1]
b. 1822 d. 24 May 1841
12
Amelia Prudence Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.2]
b. Abt 1823 d. Aug 1893 [
=>
]
12
Eliza Ann Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.3]
b. 1825 d. 1898 [
=>
]
12
Julina Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.4]
b. 1827 d. 1829
12
Harriet L. Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.5]
b. 1828 d. 1885 [
=>
]
12
Henry N. Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.6]
b. Oct 1828 d. 1904 [
=>
]
12
Charles C. Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.7]
b. 1832 d. Aft 26 Jun 1880 [
=>
]
12
Susan M. Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.2.8]
b. 1838 d. 12 Sep 1887
11
Jasper Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.3]
b. 9 Mar 1802 d. 20 Aug 1840
11
Dency Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.4]
b. 13 Dec 1803 d. 24 Jan 1879
11
William Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.5]
b. 25 Jun 1806 d. 1839
11
Alanson Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.6]
b. 26 Jul 1808 d. 29 Dec 1869
11
Deacon Hayden Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.7]
b. 13 Sep 1810 d. 6 Dec 1894
11
Harriet Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.8]
b. 19 Mar 1813 d. 4 Feb 1890
11
Coy Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.9]
b. 2 Feb 1815 d. 29 Mar 1893
11
Charles Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.10]
b. 6 Apr 1816
11
Julina Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.2.11]
b. 11 Aug 1819 d. 21 May 1820
10
Lois Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.3]
b. 1 Oct 1776
+
Truman Messenger
b. 4 Feb 1776
10
Timothy Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4]
b. 30 Nov 1781 d. 1868
Polly Allen
b. 1787 d. 1845
11
Maria P. Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1]
b. 26 May 1806 d. 20 Jul 1883
Solomon Stirdivant, Sr.
b. Abt 1794 d. 2 Jun 1885
12
Edward Otas Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.1]
b. 11 Nov 1824 d. 1904
12
William Seymour Stirdivant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.2]
b. 3 Apr 1825 d. 30 Jul 1903
12
James Cornelius Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.3]
b. 1830
12
Minerva Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.4]
b. 1832 d. 1910
12
John J. Stirdivant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.5]
b. Abt 1833 d. 25 Nov 1877
12
Henrietta Ester Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.6]
b. 11 Nov 1829 d. 19 Mar 1917
12
Timothy A. Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.7]
b. 11 Jan 1839 d. 11 Feb 1917
12
Sarah Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.8]
b. Abt 1838
12
Polly Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.9]
b. 1845
12
Betsey Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.10]
b. 1846
12
Mary Sturdevant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.11]
b. 1847
12
George Harrison Sturdivant
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.12]
b. 17 Aug 1850 d. 3 Jun 1929
12
Solomon Sturdevant, Jr.
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.1.13]
b. Abt 1849 d. 22 Aug 1922
11
Chester F. Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.2]
b. 17 Aug 1809
11
Alvin L. Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.3]
b. 5 Aug 1811
11
Sylvester A. Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.4.4]
b. 15 Dec 1818
10
Dan Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.2.5]
b. 22 Dec 1789
9
Carmie Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.3]
b. 16 May 1749
9
Isaac Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.4]
b. 22 Apr 1753 d. 1810
9
Deacon Obed Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.5]
b. 25 Oct 1757 d. Abt 1841
9
Eber Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.6]
b. Abt 1761 d. Aft 13 Oct 1812
9
Rosanna Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.7]
b. Bef 1762
Ann ________
b. 1 Jul 1729
9
Roger Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.8]
9
Martha Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.9]
9
Job Higley
[1.1.1.4.1.1.5.6.10]
b. 31 Jul 1768 d. 1808
8
Elizabeth Higley
[1.1.1.4.1.1.5.7]
b. 1723 d. 27 Jul 1774
Rev. Gideon Mills, Sr.
b. 15 Aug 1715 d. 4 Aug 1772
9
Lt. Gideon Mills, Jr.
[1.1.1.4.1.1.5.7.1]
b. 27 Oct 1749 d. 16 Mar 1812
+
Ruth Humphrey
b. 26 Jul 1751 d. 1 Nov 1822
8
Naomi Higley
[1.1.1.4.1.1.5.8]
b. 21 May 1728 d. 1817
+
Solomon Humphrey
b. 2 May 1724 d. 1798
7
Hannah Higley
[1.1.1.4.1.1.6]
b. 22 Apr 1683 d. 8 Nov 1768
7
Joseph Higley
[1.1.1.4.1.1.7]
b. 1685 d. 3 May 1715
7
Dr. Samuel Higley
[1.1.1.4.1.1.8]
b. 1687 d. Abt May 1737
7
Mindwell Higley
[1.1.1.4.1.1.9]
b. Abt 1689 d. 1 Sep 1769
Sarah Strong
b. 14 Mar 1664/5 d. 27 May 1739
7
Sarah Higley
[1.1.1.4.1.1.10]
b. 1697
7
Nathaniel Higley
[1.1.1.4.1.1.11]
b. 12 Nov 1699 d. Sep 1773
7
Joshua Higley
[1.1.1.4.1.1.12]
b. 8 Sep 1701 d. 2 Apr 1702
7
Sgt. Josiah Higley
[1.1.1.4.1.1.13]
b. 8 Sep 1701 d. 31 May 1751
7
Abigail Higley
[1.1.1.4.1.1.14]
b. 4 Nov 1703 d. Jul 1742
7
Susannah Higley
[1.1.1.4.1.1.15]
b. 1705
+
Elisha Blackman
7
Isaac Higley
[1.1.1.4.1.1.16]
b. 20 Jul 1707
3
Henry Brewster
[1.1.2]
b. Abt 1537 d. Abt 1600
2
Christopher Man
[1.2]